G:\WPNET\GAZETTE\2014\Part I\issue 07.wpd

PART I / PARTIE I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest
2014-07-31
ISSN 0225-5898 (Print / texte imprimé)
ISSN 2291-0409 (Online / en ligne)
NOTICE
AVIS
The full text of an appointment may be viewed at the
Office of the Registrar of Regulations, 4th floor
Courthouse, Yellowknife, NT X1A 2L9.
Le texte intégral d’une nomination peut être examiné au
bureau du registraire des règlements, Palais de Justice,
4e étage, Yellowknife (NT) X1A 2L9.
APPOINTMENTS / NOMINATIONS
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As Director of Adoptions under the Adoption Act:
Directeur des adoptions en vertu de la Loi sur l’adoption :
LANGFORD, Andrew
Yellowknife
A-325-2014
2014-06-18
As deputy registrar in bankruptcy under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada):
Registraire adjointe en matière de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) :
O’CONNOR, Tammie
Yellowknife
A-336-2014
2014-06-16
As Director of Child and Family Services under the Child and Family Services Act:
Directeur des services à l’enfance et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille :
LANGFORD, Andrew
Yellowknife
A-326-2014
149
2014-06-18
Part I / Partie I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As coroners for the Northwest Territories under the Coroners Act:
Coroners des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les coroners :
BURKE, Patrick
JOHNSON, Dudley
Fort Smith
Norman Wells
A-335-2014
A-338-2014
3 years/3 ans
3 years/3 ans
2014-06-25
2014-08-23
4 months/4 mois
from/de 2014-06-17
to/à 2015-06-16
2014-07-09
2014-06-17
As probation officers under the Corrections Act:
Agents de probation en vertu de la Loi sur les services correctionnels :
O’NEILL, Margaret
SIMMS, Matthew
Inuvik
Yellowknife
A-346-2014
A-347-2014
As a councillor of the Council of the Institute under the Institute of Chartered Accountants Act:
Conseiller du conseil de l’Institut en vertu de la Loi sur l’Institut des comptable agréés :
WIEST, Geoffrey P.
Yellowknife
A-337-2014
3 years/3 ans
2014-07-09
As deputy clerks of the Supreme Court of the Northwest Territories under the Judicature Act:
Greffières adjointes de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire :
MCKAY-LAROCQUE, Savanna
Dawn
O’CONNOR, Tammie
Yellowknife
A-339-2014
2014-06-16
Yellowknife
A-340-2014
2014-06-16
As Deputy Registrars of the Court of Appeal under the Judicature Act:
Registraires adjointes de la Cour d’appel en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire :
MCKAY-LAROCQUE, Savanna
Dawn
O’CONNOR, Tammie
Yellowknife
A-341-2014
2014-06-16
Yellowknife
A-342-2014
2014-06-16
As deputy Sheriffs under the Judicature Act:
Shérifs adjoints en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire :
COULTER, Robert Douglas
MCKAY-LAROCQUE, Savanna
Dawn
O’CONNOR, Tammie
Yellowknife
Yellowknife
A-343-2014
A-344-2014
2014-06-16
2014-06-16
Yellowknife
A-345-2014
2014-06-16
As chairperson of the Liquor Licensing Board under the Liquor Act:
Président de la Commission des licences d’alcool en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées :
BAILE, Colin
Yellowknife
A-303-2014
from/de 2014-06-07
to/à 2017-06-06
2014-06-07
As a member of the Liquor Licensing Board under the Liquor Act:
Membre de la Commission des licences d’alcool en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées :
BAILE, Colin
Yellowknife
A-302-2014
150
3 years/3 ans
2014-06-07
Part I / Partie I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As an issuer of marriage licences under the Marriage Act:
Délivreuse de licences de mariage en vertu de la Loi sur le mariage :
MARION, Giselle Marie
A-322-2014
Behchokö
2014-06-16
As marriage commissioners under the Marriage Act:
Commissaires aux mariages en vertu de la Loi sur le mariage :
ABERNETHY, David Richard
Yellowknife
A-328-2014
BRADEN, Seamus William
Mill Bay, BC
A-329-2014
GIBB, Beverly
Hay River
A-333-2014
from/de 2014-07-01
to/à 2014-07-31
from/de 2014-07-15
to/à 2014-08-15
2014-07-01
2014-07-15
2014-08-01
As a member of the Medical Registration Committee under the Medical Profession Act:
Membre du comité d’inscription des médecins en vertu de la Loi sur les médecins :
GUTHRIE, Dr. Bing
Yellowknife
A-334-2014
2 years/2 ans
2014-08-30
As Director under the Mental Health Act:
Directeur en vertu de la Loi sur la santé mentale :
LANGFORD, Andrew
Yellowknife
A-327-2014
2014-06-18
A-319-2014
2014-06-11
A-331-2014
2014-05-13
A-332-2014
2014-05-13
As an inspector under the Pesticide Act:
Inspecteur en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires :
MARTIN, Michael William
Arthur
Yellowknife
As Registrar under the Petroleum Resources Act:
Directrice en vertu de la Loi sur les hydrocarbures :
JENNINGS, Anne-Marie
Inuvik
As Deputy Registrar under the Petroleum Resources Act:
Directeur adjoint en vertu de la Loi sur les hydrocarbures :
BUTTERS, Ian
Inuvik
As an airport manager under the Public Airports Act:
Directeur d’aéroports en vertu de la Loi sur les aéroports publics :
KING, Karen Marie
Inuvik
A-330-2014
2014-06-01
As a public health officer under the Public Health Act:
Administratrice de la santé publique en vertu de la Loi sur la santé publique :
FORDE-SOBERS, Mercedes
Destinee Chantae
Toronto, ON
A-323-2014
151
from/de 2014-06-10
to/à 2014-09-08
2014-06-10
Part I / Partie I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As park officers under the Territorial Parks Act:
Agents des parcs en vertu de la Loi sur les parcs territoriaux :
BROWN, Greg
Yellowknife
A-304-2014
DENNILL, Cory
Yellowknife
A-305-2014
FORTNER, Jess
FUDGE, Jamie
Norman Wells
Yellowknife
A-306-2014
A-307-2014
GARBOWICZ, Michael
Yellowknife
A-308-2014
GORDON, Glen
HAMLYN, Paul
KOKO, Anne
LAROCQUE, Frank
Inuvik
Yellowknife
Inuvik
Fort Smith
A-309-2014
A-310-2014
A-311-2014
A-312-2014
MADSEN, Lukas
Yellowknife
A-313-2014
MANDEVILLE, Belinda
Hay River
A-314-2014
ROSSOUW, Max
THOM, Bradley
Yellowknife
Fort Smith
A-315-2014
A-316-2014
TONKA, Enos
Fort Simpson
A-317-2014
WILLIAMS, James
Yellowknife
A-318-2014
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
from/de 2014-05-15
to/à 2014-10-31
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
2014-05-15
As Registrar General of Vital Statistics under the Vital Statistics Act:
Registraire générale de l’état civil en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil :
ANAWAK, Jennifer Lynn
Inuvik
A-324-2014
from/de 2014-07-21
to/à 2015-07-19
2014-07-21
As a wildlife guardian under the Wildlife Act:
Garde-chasse en vertu de la Loi sur la faune :
DOUGLAS, Robert Sholto
Fort Smith
A-348-2014
from/de 2014-07-02
to/à 2014-09-30
2014-07-02
As members of the Fort Liard Youth Justice Committee under the Youth Justice Act and Youth Criminal Justice Act
(Canada):
Membres du comité de justice pour la jeunesse de Fort Liard en vertu de la Loi sur le système de justice pour les
adolescents et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) :
HOPE, Eva
LOMEN, Lucy
Fort Liard
Fort Liard
A-320-2014
A-321-2014
3 years/3 ans
3 years/3 ans
2014-06-16
2014-06-16
As youth workers under the Youth Justice Act and Youth Criminal Justice Act (Canada):
Délégués à la jeunesse en vertu de la Loi sur le système de justice pour les adolescents et la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (Canada) :
O’NEILL, Margaret
SIMMS, Matthew
Inuvik
Yellowknife
A-349-2014
A-350-2014
152
4 months/4 mois
from/de 2014-06-17
to/à 2015-06-16
2014-07-10
2014-06-17
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
REVOCATIONS / RÉVOCATIONS
Name/Nom
Revocation No./
No de révocation
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
Original Appointment/
Première nomination
ADOPTION ACT - Director of Adoptions
LOI SUR L’ADOPTION - directeur des adoptions
LANGFORD, Andrew
AR-143-2014
2014-06-16
A-094-2014
CHILD AND FAMILY SERVICES ACT - Child Protection Worker for the Northwest Territories
LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE - préposé à la protection de l’enfance des Territoires
du Nord-Ouest
MARONGWE, Honest Andy
AR-140-2014
2014-06-06
A-066-2014
CHILD AND FAMILY SERVICES ACT - Director of Child and Family Services
LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE - directeur des services à l’enfance et à la famille
LANGFORD, Andrew
AR-142-2014
2014-06-16
A-093-2014
JUDICATURE ACT - deputy clerk of the Supreme Court of the Northwest Territories
LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE - greffier adjoint de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
WILLOWS, Jeffrey Thomas
AR-148-2014
2014-06-02
A-192-2013
JUDICATURE ACT - Deputy Registrar of the Court of Appeal
LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE - registraire adjoint de la Cour d’appel
WILLOWS, Jeffrey Thomas
AR-149-2014
2014-06-02
A-193-2013
2014-06-02
A-191-2013
2014-06-16
A-095-2014
2014-05-13
A-186-2014
2014-05-13
A-187-2014
JUDICATURE ACT - deputy Sheriff
LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE - Shérif adjoint
WILLOWS, Jeffrey Thomas
AR-150-2014
MENTAL HEALTH ACT - Director
LOI SUR LA SANTÉ MENTALE - directeur
LANGFORD, Andrew
AR-141-2014
PETROLEUM RESOURCES ACT - Registrar
LOI SUR LES HYDROCARBURES - directeur
BUTTERS, Ian
AR-146-2014
PETROLEUM RESOURCES ACT - Deputy Registrar
LOI SUR LES HYDROCARBURES - directeur adjoint
LENNIE, Johnny
AR-147-2014
153
Part I / Partie I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Name/Nom
Revocation No./
No de révocation
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
Original Appointment/
Première nomination
PUBLIC AIRPORTS ACT - airport manager
LOI SUR LES AÉROPORTS PUBLICS - directrice d’aéroports
MACNEIL, Jason Randy
AR-145-2014
2014-06-01
A-061-2014
SOCIAL ASSISTANCE ACT - Social Welfare Officer for the Northwest Territories
LOI SUR L’ASSISTANCE SOCIALE - agente du bien-être social des Territoires du Nord-Ouest
TAYLOR, Cathy
AR-152-2014
2014-07-02
A-334-2010
2014-07-09
A-262-2003
TERRITORIAL COURT ACT - deputy territorial judge
LOI SUR LA COUR TERRITORIALE - juge territorial adjoint
SMITH, The Hon. / L’hon.
Thomas C.
AR-151-2014
VITAL STATISTICS ACT - Registrar General of Vital Statistics
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL - registraire générale de l’état civil
DAY, Jenetta
AR-144-2014
2014-07-20
154
A-037-2011
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
GOVERNMENT NOTICES (REGISTRIES) / AVIS DU GOUVERNEMENT (BUREAUX D’ENREGISTREMENT)
BUSINESS CORPORATIONS ACT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
NOTICES OF INCORPORATION OF TERRITORIAL CORPORATIONS (section 8):
AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES (article 8) :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Registered Office/
Bureau enregistré
Date of Incorporation/
Date de la constitution
TUNDRA HARVEST
NWT INC.
506775
21 Trails End
Yellowknife NT
X1A 1A4
2014-06-11
TLICHO
INDUSTRIAL
SUPPLY LTD.
506776
121 Curry Drive
P.O. Box 2172
Yellowknife NT
X1A 2P6
2014-06-18
NRC ENERGY
SERVICES LTD.
506777
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-06-20
A.G.L. FLOORING
LTD.
506778
121 Curry Drive
P.O. Box 2172
Yellowknife NT
X1A 2P6
2014-06-27
POLAR ENERGY
SOLUTIONS INC.
506779
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-06-30
506780 N.W.T. LTD.
506780
170 Mackenzie Road
P.O. Box 1700
Inuvik NT X1A 0T0
2014-07-02
506781 N.W.T. LTD.
506781
170 Mackenzie Road
P.O. Box 1700
Inuvik NT X1A 0T0
2014-07-02
NOTICES OF AMENDMENT OF ARTICLES OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 29(6) or section 180]:
AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 29(6) ou
article 180] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Amendment/
Date de la modification
NORTH VENTURES LTD.
505469
2014-06-02
155
Part I / Partie I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
NOTICES OF DISSOLUTION OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 212(5)]:
AVIS DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 212(5)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Dissolution/
Date de la dissolution
CARIBOU MOTOR INN LTD.
500124
2014-06-17
BRAZEAU REPAIRS LTD.
502484
2014-06-13
I & D MANAGEMENT
SERVICES LTD.
505041
2014-06-12
SAHTUGOT'INE
CONSTRUCTION LTD.
506119
2014-06-11
ITB TULU LTD.
506577
2014-06-19
NOTICES OF DISSOLUTION OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 214(6)]:
AVIS DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 214(6)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Dissolution/
Date de la dissolution
5885 NWT INC.
505885
2014-06-25
NOTICES OF DISSOLUTION OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 225(7)]:
AVIS DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 225(7)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Dissolution/
Date de la dissolution
BEAUFORT
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES INC.
505388
2014-06-12
NOTICES OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 285(1)]:
AVIS D’ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 285(1)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société
par actions
Registered Office/
Bureau enregistré
Jurisdiction/
Autorité législative
Date of Registration/
Date de l’enregistrement
M. SIGVALDASON
REFRIGERATION
INC.
611254
Suite 802
Northwest Tower
5201 50th Avenue
Yellowknife NT
X1A 3S9
Manitoba
2014-06-04
1805144 ALBERTA
LTD.
611255
301 Nunasi Building
5109 48th Street
Yellowknife NT
X1A 1N5
Alberta
2014-06-04
156
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
1809504 ALBERTA
LTD.
611256
301 Nunasi Building
5109 48th Street
Yellowknife NT
X1A 1N5
Alberta
2014-06-05
VERTICAL SCREEN
CANADA, INC.
611257
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
Canada
2014-06-05
FIELDPRINT
CANADA, INC.
611258
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
Canada
2014-06-05
ACHO DENE
KOE / NCSG
CRANE AND
HEAVY HAUL
LTD.
611260
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Alberta
2014-06-06
BLOOM BURTON &
CO. LIMITED
611261
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
Ontario
2014-06-12
MCLEAN
VEGETATION
SERVICES LTD.
611262
Suite 5
6 Courtoreille Street
Hay River NT
X0E 1G2
Alberta
2014-06-12
MHPM PROJECT
MANAGERS
INC. / MHPM
GESTION DE
PROJECT INC.
611263
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Canada
2014-06-13
STANDARD LIFE
MUTUAL FUNDS
LTD. / FONDS DE
PLACEMENT
STANDARD LIFE
LTÉE
611266
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Canada
2014-06-26
SECURE ENERGY
(DRILLING
SERVICES) INC.
611267
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Alberta
2014-06-26
157
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
NOTICES OF CHANGE OF NAME OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 289(4)]:
AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
EXTRATERRITORIALES [paragraphe 289(4)] :
Name of Corporation/
Dénomination sociale
de la société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
New Name of Corporation/
Nouvelle dénomination
sociale de la société par
actions
Effective Date/
Date de prise d’effet
GRACOM MASONRY
LTD.
607846
BRXTON
CONSTRUCTION
LTD.
2014-05-01
GE CONSUMER
FINANCE CANADA
COMPANY
608078
SYNCHRONY
FINANCIAL
CANADA COMPANY
2014-06-02
MJR COLLECTION
SERVICES LIMITED
608271
MJR CAPITAL
SERVICES INC.
2014-04-10
STUART OLSON
DOMINION
CONSTRUCTION
LTD.
608347
STUART OLSON
CONSTRUCTION
LTD.
2014-05-28
GE MONEY
HOLDING
COMPANY /
SOCIÉTÉ DE
PORTEFEUILLE
MONÉTAIRE GE
608519
SYNCHRONY
HOLDING
COMPANY
2014-06-02
SCOTIA INSURANCE
AGENCY
INC. / AGENCE
D'ASSURANCES
SCOTIA INC.
609779
BNS INSURANCE
AGENCY
INC. / AGENCE
D'ASSURANCES BNE
INC.
2014-05-22
MACRO NORTH
AMERICAN
PIPELINE INC.
610812
MACRO PIPELINES
INC.
2014-06-01
SONY DADC CANADA
INC.
611265
SONY MUSIC
ENTERTAINMENT
CANADA INC.
2014-04-01
158
Part I / Partie I
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
NOTICES OF AMALGAMATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 290(2)]:
AVIS DE FUSION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 290(2)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société
par actions
Amalgamating Corporations/
Sociétés par actions fusionnées
Date of Amalgamation/
Date de la fusion
IPC INVESTMENT
CORPORATION
611253
610403: IPC INVESTMENT
CORPORATION;
INDEPENDENT PLANNING
GROUP INC. / GROUPE
INDEPENDANT DE
PLANIFICATION INC.
2014-05-01
WEYERHAEUSER
COMPANY
LIMITED /
COMPAGNIE
WEYERHAEUSER
LIMITEE
611259
607043: WEYERHAEUSER
COMPANY LIMITED /
COMPAGNIE WEYERHAEUSER
LIMITEE; 8684227 CANADA INC.
2013-11-30
CONGREGATION
OF THE SISTERS
OF ST. JOSEPH
IN CANADA
611264
604317: THE SISTERS OF
ST. JOSEPH OF THE DIOCESE OF
LONDON, IN ONTARIO;
THE SISTERS OF ST. JOSEPH OF
HAMILTON; THE SISTERS OF
ST. JOSEPH OF THE DIOCESE OF
PETERBOROUGH IN ONTARIO;
THE SISTERS OF ST. JOSEPH FOR
THE DIOCESE OF PEMBROKE IN
CANADA
2013-06-13
SONY MUSIC
ENTERTAINMENT CANADA
INC.
611265
608677: SONY MUSIC
ENTERTAINMENT CANADA INC.;
SONY DADC CANADA INC.
2014-04-01
NOTICES OF PROPOSED CANCELLATION OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS
[paragraph 294(3)b)]:
AVIS DE PROJET D’ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
EXTRATERRITORIALES [alinéa 294(3)(b)]:
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Notice/
Date de l’avis
CITI TRUST COMPANY
CANADA
610176
2014-06-11
TAKHAR COLLECTION
SERVICES LTD.
608667
2014-06-11
159
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
NOTICES OF CANCELLATION OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS
[subsection 294(6)]:
AVIS D’ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES
[paragraphe 294(6)]:
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Cancellation/
Date de l’annulation
VIKING YELLOWKNIFE
GOLD MINES LIMITED
600568
2014-07-02
SPUR AVIATION LTD.
601402
2014-07-02
B.J. ASHTON, PROFESSIONAL
CORPORATION
602249
2014-07-02
ARDIC EXPLORATION AND
DEVELOPMENT LTD., INC.
603228
2014-07-02
NATIVE GOSPEL OUTREACH
603545
2014-07-02
HIGHROCK CONTRACTING
LTD.
604047
2014-07-02
SAHTU CONTRACTORS LTD.
604091
2014-07-02
SHATTLER PAINTING INC.
604118
2014-07-02
FORT SIMPSON METIS
DEVELOPMENT
CORPORATION
604257
2014-07-02
BEAU DEL AIR LTD.
604673
2014-07-02
ULA SERVICE LIMITED
604802
2014-07-02
SORA GROUP WEALTH
ADVISORS INC.
609072
2014-06-19
C.A.S.M. ENTERPRISES LTD.
609101
2014-06-10
GREAT BEAR RESOURCES
LTD.
609315
2014-06-12
HIGHSTREET ARCTIC
SUNSET GENERAL
PARTNER INC.
610423
2014-06-12
1772174 ONTARIO INC.
611057
2014-06-19
SÉCURIGLOBE INC.
611188
2014-07-02
160
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
SOCIETIES ACT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS
NOTICES OF INCORPORATION OF SOCIETIES [subsection 4(4)]:
AVIS DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE [paragraphe 4(4)] :
Name/
Dénomination sociale
Incorporation No./
No de constitution
Location of Operations/
Lieu d'exercice des
activités
Incorporation Date/
Date de constitution
FREEDOM
FOUNDATION
701933
Yellowknife
2014-06-30
NOTICES OF DISSOLUTION OF SOCIETIES (section 27):
AVIS DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS (article 27) :
Name/
Dénomination sociale
Incorporation No./
No de constitution
Dissolution Date/
Date de dissolution
INUVIK ALCOHOL
COMMITTEE
700375
2014-06-06
INUVIK PRESCHOOL
SOCIETY
700695
2014-06-30
THE WESTERN ARCTIC
LEADERSHIP PROGRAM
700990
2014-06-06
WHA TI DEVELOPMENT
701115
2014-06-06
INUVIK REGIONAL HEALTH
AND SOCIAL SERVICES
FOUNDATION
701521
2014-06-06
HAY RIVER JET BOAT RACE
COMMITTEE
701527
2014-06-30
TOT SPOT
701705
2014-06-30
161
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
GOVERNMENT NOTICES (MISCELLANEOUS) / AVIS DU GOUVERNEMENT (DIVERS)
EVIDENCE ACT
LOI SUR LA PREUVE
Appointments and reappointments (R) of Commissioners for Oaths:
Nominations et renominations (R) de commissaires aux serments :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
ALLDRIDGE, Ferial (R)
BROWNING, Rosie J.
CROCKER, Darren Mark (R)
ELDER, Louise Mae
HEWLKO, Sonia Anna (R)
JONES, Kristy
KILPATRICK, Lana Marion
SAVARD, Andree
WOLDUM, Kristen Phyllis (R)
Inuvik
Hay River
Edmonton
Yellowknife
Yellowknife
Fort Smith
Inuvik
Behchokö
Yellowknife
Appointments and reappointments (R) of Notaries Public:
Nominations et renominations (R) de notaires publics :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
CASH, Alan (R)
EGGENBERGER, Wendy Jeanne (R)
FORCADE, Lauri Anne
LEONARDIS, Dorothy Gail (R)
MATHESON, Kym Zoe (R)
MIRZA, Jasmin
MORLEY, Allison Emma
MOULD, Robin Anne (R)
ORLIAS, Ann Margaret
RUIZ, Barbara Ann (R)
TEREPOSKY, Andrew
WALSH, Trudie A. (R)
Yellowknife
Yellowknife
Inuvik
Yellowknife
Norman Wells
Yellowknife
Yellowknife
Yellowknife
Colville Lake
Yellowknife
Yellowknife
Hay River
162
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
CHANGE OF NAME ACT / LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM
The following changes of names have been registered under the Change of Name Act and are hereby published in accordance with section 14 of that Act: /
Les changements de nom qui suivent ont été enregistrés en application de la Loi sur le changement de nom et sont, par les présentes, publiés en conformité avec l’article 14 de
cette loi.
FORMER SURNAME / GIVEN NAMES
ANCIEN NOM DE FAMILLE /
ANCIENS PRÉNOMS
DATE OF BIRTH
(dd/mm/yyyy) /
DATE DE
NAISSANCE
(jour/mois/année)
COMMUNITY OF
RESIDENCE /
COLLECTIVITÉ
OÙ LA PERSONNE
RÉSIDE
REVISED NAME
(SURNAME/GIVEN) /
NOUVEAU NOM
(NOM DE FAMILLE/PRÉNOMS)
EFFECTIVE DATE
(dd/mm/yyyy) /
DATE DE PRISE
D’EFFET
(jour/mois/année)
Wick/Randi Therese Marie
26/07/1994
Yellowknife
Wick/Malek Randolph Virgil
10/06/2014
Lance/Natasia
08/08/1976
Fort Smith
Tourangeau/Natashia Victoria
13/06/2014
163
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
MISCELLANEOUS NOTICES/AVIS DIVERS
NOTICE OF PUBLIC AUCTION
Pursuant to Section 97.7(2) of the Property Assessment and Taxation Act, R.S.N.W.T. 1988, c. P-10 and amendments thereto, the
Municipal Corporation of the Town of Norman Wells wishes to advise that the following properties may be offered for public auction
if the arrears of property taxes and the current and subsequent expenses incurred by the Town to collect the arrears are not paid before
September 9, 2014:
LOT
GROUP
PLAN
MINIMUM AUCTION
PRICE
165
166
275
1158
1158
1170
1170
1522
$ 35,023.06
$ 33,852.47
$ 31,350.00
164
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
AVIS DE VENTE DE PROPRIÉTÉS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
En application du paragraphe 97.7(2) de la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-10, telle que modifiée,
la municipalité de la ville de Norman Wells annonce que les propriétés suivantes seront mises en vente aux enchères publiques si
les arriérés d’impôt foncier et les dépenses engagées par la ville jusqu’au 9 septembre 2014 pour la perception de ces arriérés ne sont
pas remboursés à cette date :
LOT
GROUPE
PLAN
PRIX D’ENCHÈRE
MINIMAL
165
166
275
1158
1158
1170
1170
1522
35 023,06 $
33 852,47 $
31 350,00 $
165
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Please be advised of the following:
The public auction is set for September 9, 2014, at Council Chambers, Town Hall, Norman Wells, NT, at 10:00 a.m.
All properties are sold as is. Any purchaser shall be required to comply with the Town’s Property Standards Bylaw at the purchaser’s
own expense.
If prior to commencement of public auction, any person including the assessed owner pays the arrears of property taxes and all
reasonable expenses incurred by the Town of Norman Wells to collect the arrears with respect to a taxable property, the property will
not be offered for auction.
Any person who pays the arrears of property taxes and expenses prior to commencement of the public auction may obtain a lien on
the taxable property for the amount paid if that person is not the assessed owner and that person has an interest, estate, encumbrance
or claim registered or filed under the Land Titles Act in or against the taxable property or is a transferee of such a person.
The assessed owner of any of the above taxable properties is entitled to redeem that taxable property within 30 days after the date
of the public auction by paying the Town of Norman Wells the arrears of property taxes and all reasonable expenses incurred by the
incurred by the Town of Norman Wells to collect the arrears. Where a taxable property that is sold at the public auction is redeemed
by its assessed owner, the sale cannot be completed and all rights and interests of the purchaser in the taxable property cease.
If a taxable property is sold at the public auction, every existing interest, estate, encumbrance or claim in or against the taxable
property, will be extinguished, other than:
- a caveat registered under the Land Titles Act in respect of
- a restrictive covenant;
- an easement, including a utility easement;
- an easement agreement, including a party wall agreement;
- a restrictive covenant or an easement, including a utility easement;
- an easement agreement, including a party wall agreement;
- a reservation or interest to which the property is subject under paragraphs 69(a), (c) and (d) of the Land Titles Act;
- an interest, estate, encumbrance or claim of Her Majesty in right of Canada;
- an interest, estate, encumbrance, or claim that is prescribed or of a prescribed class.
MCLENNAN ROSS LLP
Barristers & Solicitors
301-5109 48th Street
Yellowknife, NT X1A N51
Phone: (867) 766-7680
Attention: Edward Gullberg
166
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Soyez avisés que :
La vente aux enchères aura lieu à 10 h, le 9 septembre 2014 à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Norman Wells, T.N.-O.
Toutes les propriétés sont vendues telles quelles. Tout acheteur peut être tenu de se conformer au Règlement municipal sur les
normes de propriété et le tout, à ses propres frais.
La propriété ne sera pas mise en vente aux enchères si, avant le début des enchères publiques, quelqu’un, y compris le propriétaire
évalué, rembourse les arriérés d’impôt foncier et toutes les dépenses raisonnables engagées par la ville de Norman Wells pour la
perception de ces arriérés.
À l’exception du propriétaire évalué, la personne qui rembourse les arriérés d’impôt foncier et les dépenses, avant le début des
enchères publiques, et qui a un intérêt, un domaine, une charge ou une réclamation enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur les
titres de biens-fonds à l’égard de la propriété imposable, ou le cessionnaire de cette personne, peut avoir un privilège sur la propriété
imposable pour le montant remboursé.
Le propriétaire évalué d’une propriété imposable vendue aux enchères publiques peut, dans les 30 jours suivant les enchères
publiques, racheter la propriété imposable en remboursant la ville de Norman Wells les arriérés d’impôt foncier et les dépenses
raisonnables engagées par cette dernière pour la perception de ces arriérés. Lorsqu’une propriété imposable vendue aux enchères
publiques est ainsi rachetée par son propriétaire évalué, la vente aux enchères ne peut être conclue et les droits et intérêts de l’acheteur
dans la propriété sont éteints.
La vente aux enchères publiques d’une propriété imposable éteint tout intérêt, domaine, charge ou réclamation à l’égard de cette
propriété, sauf :
- une opposition enregistrée en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds relativement à :
- une clause restrictive;
- une servitude, y compris une servitude d’utilité publique;
- une entente visant une servitude, y compris une entente visant un mur mitoyen;
- une clause restrictive ou une servitude, y compris une servitude d’utilité publique;
- une entente visant une servitude, y compris une entente visant un mur mitoyen;
- une clause de réserve ou un intérêt dont la propriété fait l’objet aux termes des alinéas 69a), c) et d) de la Loi sur les titres
de biens-fonds;
- tout intérêt, domaine, charge ou réclamation de Sa Majesté du chef du Canada;
- tout intérêt, domaine, charge ou réclamation prescrit ou d’une catégorie prescrite.
MCLENNAN ROSS LLP
Avocats et conseillers juridiques
301, 5109 48e Rue
Yellowknife T.N.-O. X1A 1N5
Téléphone : (867) 766-7680
Attention : Edward Gullberg
167
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Printed by
Territorial Printer, Northwest Territories
Yellowknife, N.W.T./2014©
Volume 35, No. 7 / Volume 35, no 7
Imprimé par
l’imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest
Yellowknife (T. N.-O.)/2014©
168